Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
---|---|---|
Determinazione del Responsabile 605 19-05-2016 |
RETROCESSIONE LOTTO N. 4 LOC. RIO CHITARRINO FORNCI DI BARGA. DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA CARROZZERIA GIGLI SNC. |
|
Determinazione del Responsabile 685 29-05-2014 |
RETTICA determinazione n. 656 del 27/05/14 "Eventi alluvionali 20-21 ottobre 2013 L.R. 72/2013 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' Impegno e liquidazione - Atto n. 1- " |
|
Determinazione del Responsabile 216 25-02-2014 |
RETTIFICA Determinazione n.100 del 30/01/2014 |
|
Determinazione del Responsabile 222 25-02-2014 |
RETTIFICA Determinazione n.166 del 15/02/2014 |
|
Deliberazione di Giunta Comunale 140 29-11-2022 |
RETTIFICA DELIBERA G.C. n. 134/2022 - Adeguamento funzionale energetico e normativo degli spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo "L. Orlando" di Fornaci di Barga - CUP C18E22000150002 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. |
|
Deliberazione di Giunta Comunale 46 19-04-2022 |
RETTIFICA DELIBERA G.C. n. 38/22 relativa a "Adeguamento antincendio della scuola elementare di Filecchio - CUP C16B19000910002 - e della scuola media in Fornaci di B. - CUP C16B19001100008 - Atto ricognitivo intervento ed approvazione nuovo progetto". |
|
Deliberazione di Giunta Comunale 80 21-05-2015 |
RETTIFICA DELIBERA G.M. N 75 DEL 15.05.2015. |
|
Deliberazione di Giunta Comunale 163 02-12-2010 |
RETTIFICA DELIBERAZIONE G.M. N. 157 DEL 16.11.2010 |
|
Determinazione del Responsabile 902 01-08-2018 |
RETTIFICA DET. n. 761 DEL 21/06/2018 - Implementazione sistema di videosorveglianza - CUP C17G17000050006 - CIG Z57216831E - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE. |
|
Determinazione del Responsabile 1044 05-09-2018 |
RETTIFICA DETERMINA N. 1032 DEL 3/9/18 -Efficientamento energetico dell'edificio: scuola media Don Aldo Mei di Barga - impegno di spesa a favore di Edison Energia. |
|
Determinazione del Responsabile 543 03-05-2016 |
RETTIFICA DETERMINA N. 1498 DEL 20.11.2014 SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE ANNO 2014. |
|
Determinazione del Responsabile 1784 31-12-2014 |
RETTIFICA DETERMINA N. 1769 DEL 30/12/2014 |
|
Determinazione del Responsabile 353 20-03-2014 |
RETTIFICA DETERMINA N. 285 DEL 7/3/14 "Manutenzione ordinaria scuole e patrimonio disponibile - Liquidazione fatture" |
|
Determinazione del Responsabile 454 11-04-2014 |
RETTIFICA DETERMINA N. 438 DEL 7.4.2014 AVENTE AD OGGETTO:LIQUIDAZIONE SALDO ALL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI RELATIVI ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE RURALI ED INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE EDILIZIE RICORRENTI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. |
|
Determinazione del Responsabile 754 12-06-2014 |
RETTIFICA DETERMINA N. 461/14. |
|
Determinazione del Responsabile 673 30-05-2013 |
RETTIFICA DETERMINA N. 558 DEL 2/5/13 - Adeguamento sismico scuola materna in Fornaci di Barga - Opere in elevazione. - LIQUIDAZIONE 2' SAL - |
|
Determinazione del Responsabile 885 28-08-2020 |
RETTIFICA DETERMINA N. 760 DEL 03/08/2020 - DIVISIONE SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI IN DUE DISTINTI LOTTI (TARI - UTENZE DOMESTICHE E TARI - AZIENDE). REVOCA PARZIALE AFFIDAMENTO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI -AZIENDE E NUOVO AFFIDAMENTO DELLO STESSO CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
Determinazione del Responsabile 1295 15-10-2014 |
RETTIFICA DETERMINA N. 799 DEL 19/6/14 " MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E PATRIMONIO DISPONIBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE". |
|
Determinazione del Responsabile 1031 11-08-2015 |
RETTIFICA DETERMINA N. 938 "ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - ACQUISTO STAMPATI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA" |
|
Determinazione del Responsabile 1011 06-08-2015 |
RETTIFICA DETERMINA N. 939 "ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA" |
|