Main Content

Elenco atti decisionali

Ricerca
 
 

27.326 atti trovati

Browse

Atto Oggetto del documento Altri dati
Determinazione del Responsabile
605
19-05-2016
RETROCESSIONE LOTTO N. 4 LOC. RIO CHITARRINO FORNCI DI BARGA. DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA CARROZZERIA GIGLI SNC.
 
Determinazione del Responsabile
685
29-05-2014
RETTICA determinazione n. 656 del 27/05/14 "Eventi alluvionali 20-21 ottobre 2013 L.R. 72/2013 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' Impegno e liquidazione - Atto n. 1- "
 
Determinazione del Responsabile
216
25-02-2014
RETTIFICA Determinazione n.100 del 30/01/2014
 
Determinazione del Responsabile
222
25-02-2014
RETTIFICA Determinazione n.166 del 15/02/2014
 
Deliberazione di Giunta Comunale
140
29-11-2022
RETTIFICA DELIBERA G.C. n. 134/2022 - Adeguamento funzionale energetico e normativo degli spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo "L. Orlando" di Fornaci di Barga - CUP C18E22000150002 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
 
Deliberazione di Giunta Comunale
46
19-04-2022
RETTIFICA DELIBERA G.C. n. 38/22 relativa a "Adeguamento antincendio della scuola elementare di Filecchio - CUP C16B19000910002 - e della scuola media in Fornaci di B. - CUP C16B19001100008 - Atto ricognitivo intervento ed approvazione nuovo progetto".
 
Deliberazione di Giunta Comunale
80
21-05-2015
RETTIFICA DELIBERA G.M. N 75 DEL 15.05.2015.
 
Deliberazione di Giunta Comunale
163
02-12-2010
RETTIFICA DELIBERAZIONE G.M. N. 157 DEL 16.11.2010
 
Determinazione del Responsabile
902
01-08-2018
RETTIFICA DET. n. 761 DEL 21/06/2018 - Implementazione sistema di videosorveglianza - CUP C17G17000050006 - CIG Z57216831E - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.
 
Determinazione del Responsabile
1044
05-09-2018
RETTIFICA DETERMINA N. 1032 DEL 3/9/18 -Efficientamento energetico dell'edificio: scuola media Don Aldo Mei di Barga - impegno di spesa a favore di Edison Energia.
 
Determinazione del Responsabile
543
03-05-2016
RETTIFICA DETERMINA N. 1498 DEL 20.11.2014 SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE ANNO 2014.
 
Determinazione del Responsabile
1784
31-12-2014
RETTIFICA DETERMINA N. 1769 DEL 30/12/2014
 
Determinazione del Responsabile
353
20-03-2014
RETTIFICA DETERMINA N. 285 DEL 7/3/14 "Manutenzione ordinaria scuole e patrimonio disponibile - Liquidazione fatture"
 
Determinazione del Responsabile
454
11-04-2014
RETTIFICA DETERMINA N. 438 DEL 7.4.2014 AVENTE AD OGGETTO:LIQUIDAZIONE SALDO ALL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI RELATIVI ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE RURALI ED INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE EDILIZIE RICORRENTI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO.
 
Determinazione del Responsabile
754
12-06-2014
RETTIFICA DETERMINA N. 461/14.
 
Determinazione del Responsabile
673
30-05-2013
RETTIFICA DETERMINA N. 558 DEL 2/5/13 - Adeguamento sismico scuola materna in Fornaci di Barga - Opere in elevazione. - LIQUIDAZIONE 2' SAL -
 
Determinazione del Responsabile
885
28-08-2020
RETTIFICA DETERMINA N. 760 DEL 03/08/2020 - DIVISIONE SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI IN DUE DISTINTI LOTTI (TARI - UTENZE DOMESTICHE E TARI - AZIENDE). REVOCA PARZIALE AFFIDAMENTO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI -AZIENDE E NUOVO AFFIDAMENTO DELLO STESSO CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazione del Responsabile
1295
15-10-2014
RETTIFICA DETERMINA N. 799 DEL 19/6/14 " MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E PATRIMONIO DISPONIBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE".
 
Determinazione del Responsabile
1031
11-08-2015
RETTIFICA DETERMINA N. 938 "ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - ACQUISTO STAMPATI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA"
 
Determinazione del Responsabile
1011
06-08-2015
RETTIFICA DETERMINA N. 939 "ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA"
 
 

Browse